Skip to main content

Name Index – 1005

<!–p1004">Previous Page

  • Next –>
  • Cox (cont.)
    Rufus Edward Secker  b. 14 Mar 2005
    Rupert Lyttelton  b. 4 Sep 1956
    Ruth  d. 1946
    Samuel Compton  b. c 1758, d. 25 Mar 1839
    Samuel Lawrence  b. 5 Apr 1810, d. 1865
    Sara  b. 1784
    Sarah Alice  b. 14 Nov 1948
    Sarah Elizabeth  b. 17 Apr 1960
    Sarah Lamorna  b. 4 Jun 1957
    Sarah Rebecca  b. 16 Sep 1855, d. 24 Aug 1892
    Sarah Shepherd  b. 1840
    Sheila Maisie  d. 1979
    Sheila Mary  b. 7 Mar 1936
    Simon  b. 10 Oct 1962
    Simon John  b. b 1981
    Stacey  b. 29 Jun 1684, d. 1738
    Susan  b. 1917, d. 2003
    Susan Elizabeth  b. 30 Jul 1961
    Susan Lian Mackintosh  b. 10 Nov 1971
    Susan Mary  b. 1961
    Susanna  d. 1806
    Susanna  b. c 1679, d. 10 Aug 1716
    Susannah Meriel  b. 1977
    Syvia  b. c 1877
    Teresa Rebecca  b. 1880
    Thomas  b. 17 Aug 1737, d. 1788
    Thomas Alexander  b. 6 Jul 2000
    Thomas Gerrard Kennedy  b. 31 Oct 1995
    Timothy Egerton  b. 28 Sep 1956
    Timothy Francis  d. 17 Nov 2017
    Timothy Michael Wilton  b. 17 Apr 1959
    Toby  b. 1974
    Victoria Tamsin  b. 25 Feb 1964
    Virginia Anne  b. 25 Jun 1935
    Walter  b. 8 Feb 1679, d. 5 Jun 1683
    Walter  b. 1915, d. 1993
    Wendy Ruth  b. 2 Dec 1948
    William  b. b 1625
    William  b. 1686, d. 1722
    William  b. 1764, d. 14 Mar 1837
    William  b. 1884, d. 1970
    William Douglas  d. 1905
    William Henry  b. 27 Jan 1821, d. 27 May 1914
    William Saurin  b. 1817, d. 28 Feb 1865
    Winifred Blanche Victoria  d. 18 Feb 1969
    Zoe  b. 1969
    Cox-Cox
    Cox-Johnson
    Celia Rosalind  b. 7 Dec 2010
    Judith Mary  d. 1997
    Richard Mark  b. 4 Oct 1934, d. 25 Mar 2005
    Cox-Sanger
    Charlotte Sophia  b. 1855, d. 1923
    Coxe
    Anita Emily Mynott  b. 30 Jun 1894, d. 15 May 1970
    Anne  d. 1850
    Charlotte Esther  b. 1805, d. 1895
    Henry Hippisley  b. 1748, d. 1795
    Henry Octavius  b. 20 Sep 1811, d. 8 Jul 1881
    Jane Teresa Louisa  d. bt 1930 – 1940
    Sarah  d. 17 Mar 1801
    Susan Esther  b. 1842, d. 1894
    Tench Francis  b. 22 May 1893, d. 18 Jan 1923
    Coxeter
    Coxey
    Ursula  b. c 1552, d. c Dec 1628
    Coxhead
    James Alfred  d. 27 Sep 1929
    Mabel Howard  d. 7 May 1950
    Mary S.  b. 1791, d. 1874
    Coxon
    Arabella Jean  b. c 1918, d. 18 Feb 2014
    Arthur Cedric Mears  d. 9 Jun 1968
    Arthur John Douglas  b. 22 Mar 1927, d. 11 Jul 2019
    Cedric  d. 9 Jun 1968
    Douglas Charles  b. 13 Nov 1952
    Emmeline Mary  d. 1964
    Helen Florence Howard  b. 9 Mar 1923
    Isabella Douglas  b. 22 Mar 1891
    Joan Elisabeth  b. 1908, d. 4 Jul 2002
    Lilian Eleanor Marie  d. 24 Nov 1973
    Mark Peter  b. 13 Aug 1954
    Michael  d. 30 Nov 1792
    Raymond  d. 1982
    Coxsed
    Anne  d. 25 Jan 1626
    Coxsedge
    Benjamin John  b. 1975
    Hannah Ruth  b. 1974
    Sherry Angela  b. 3 Nov 1946
    Coxwell
    Rachel  b. c 1555
    Coxwell-Rogers
    Aileen Emma  b. 25 Apr 1861, d. 1951
    Eleanor  d. 6 Nov 1894
    Godfrey Hugh Wheeler  d. 17 Mar 1913
    Richard Rogers  d. 31 Dec 1895
    Coy
    Benjamin William  b. 19 Nov 1967, d. 21 Nov 1967
    Georgina Anne  b. 1971
    Jolyon  b. 1985
    Rosa Susan  b. 28 Sep 1966
    Sally Amanda  b. 11 Dec 1968
    Sarah Christine  b. 1942
    Coyevinas
    Victoria  b. 23 Feb 1974
    Coyle
    Francis  d. 1982
    Nellie Kathleen  b. 30 Sep 1906
    Coyman
    Coymans
    Isabella  d. 28 Jan 1705

     

    <!– Previous Page

  • Next –>